Nouvelle recherche
1-20 de 4 918
Non disponible car vous avez appliqué un filtre de lieu, de date ou d’image

Pour de meilleurs résultats, ajoutez plus d’informations comme Prénom(s), Informations sur la naissance, Informations sur le décès et Lieu. Vous pouvez même deviner. Cela pourra aider. ou en savoir plus

  1. Information sur le document.
    Nom
    Amédée de Joinville, Seigneur de Méry, d'Aulnay, d'Soudron, d'Etrelles et du C hatel
    Naissance
    Décès
  2. Information sur le document.
    Nom
    Keensville Hotel
    Résidence
    1901-1920 Shamokin Dam, Snyder, Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis)
  3. Information sur le document.
    Nom
    1926 Group Photo Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  4. Information sur le document.
    Nom
    1926 Group Photo Detail 1 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  5. Information sur le document.
    Nom
    1926 Group Photo Detail 2 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  6. Information sur le document.
    Nom
    1926 Group Photo Detail 3 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  7. Information sur le document.
    Nom
    1926 Group Photo Detail 4 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  8. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ukster, New York, USA (États-Unis)
  9. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Detail 1 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  10. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Detail 2 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  11. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Detail 3 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  12. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Detail 4 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  13. Information sur le document.
    Nom
    1931 Group Photo Detail 5 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  14. Information sur le document.
    Nom
    C1920 Group Photo Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  15. Information sur le document.
    Nom
    C1920 Group Photo Detail 1 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  16. Information sur le document.
    Nom
    C1920 Group Photo Detail 2 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  17. Information sur le document.
    Nom
    C1920 Group Photo Detail 3 Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  18. Information sur le document.
    Nom
    C1920s Outside Activities Photo Album Funcrest Hotel Pine Hill NY
    Résidence
    1921-1940 Pine Hill, Ulster, New York, USA (États-Unis)
  1. Voir l’image
    Naissance
    xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx
    Décès
    xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxx
  2. Voir l’image
    Naissance
    x xxx xxxx xx xxxxx xxxxx
    Décès
    x xxx xxxx xx xxxx xxxxx
  3. Résidence
    1901-1920
    Shamokin Dam, Snyder, Pennsylvania (Pennsylvanie), USA (États-Unis)
Résultats 1 à 20 de 4 918
par page

Raccourci clavier

  • Alt + nNouveau
  • Alt + rAffiner
  • Alt + pPrévisualiser le document
  • Alt + ]Résultat suivant
  • Alt + [Résultat précédent